USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Methodist Guild Holidays Limited

Adresse
C/O Frp Advisory Trading Li
Ashcroft House
Ervington Court
Meridian Business
LE19 1WL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
11. Juli 2018
Firmenbuch-Nummer 00223776 Companies House Eintrag ansehen
FB StatusLiquidation
Gründungsdatum12. August 1927
JahresabschlussGROUP
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House
Albans, Keith Richard Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2017 Geburtsdatum: 05.1952 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Barwood, Ann Margaret Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2017 Geburtsdatum: 07.1941 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors
  • Bateman, Michael George Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2017 Geburtsdatum: 04.1950 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors
  • Binks, Peter Ronald Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2017 Geburtsdatum: 04.1942 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors
  • Firth, Nicola Louise Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Mills, Peter Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2017 Geburtsdatum: 06.1949 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors
  • Moffoot, John Evan Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2017 Geburtsdatum: 10.1949 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors
  • Wrench, Martin John Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2017 Geburtsdatum: 02.1945 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors
  • Mantle, Kevin Eric Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2017 Löschung: 31.12.2018 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Albans, Keith Richard Meridian Business Park, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2017 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Ordained Presbyter Of The Methodist Chur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Barwood, Ann Margaret Meridian Business Park, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2012 Geburtsdatum: 07.1941 Beschäftigung: Canon Librarian Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Bateman, Michael George Meridian Business Park, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2017 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Self Employed Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Binks, Peter Ronald Meridian Business Park, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2012 Geburtsdatum: 04.1942 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Firth, Nicola Louise Meridian Business Park, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2019 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mills, Peter Anthony Meridian Business Park, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2012 Geburtsdatum: 06.1949 Beschäftigung: Retired Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Mills, Peter Anthony Meridian Business Park, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2017 Rolle: Secretary
    Moffoot, John Evan Cromford, Matlock, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2011 Geburtsdatum: 10.1949 Beschäftigung: Retired Local Government Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wrench, Martin John Meridian Business Park, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2012 Geburtsdatum: 02.1945 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag GB Abbot Hall Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2017 Companies House Nummer: 00164520 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Christian Guild Holidays Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2017 Companies House Nummer: 02126913 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Christian Holiday Hotels Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2017 Companies House Nummer: 03288904 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Derwent House Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2017 Companies House Nummer: 00286181 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag HH Realisations 2021 Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2018 Companies House Nummer: 01847124 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Wesley Guild Holidays (London) Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2017 Companies House Nummer: 00281589 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Treloyhan Manor (South) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2020 Löschung: 28.05.2021 Companies House Nummer: 12000077 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Treloyhan Manor (South) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2020 Löschung: 28.05.2021 Companies House Nummer: 12000077 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Treloyhan Manor Park (North) Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2020 Löschung: 28.05.2021 Companies House Nummer: 12000264 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors