USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Agriteck Solutions Limited

Adresse
Harper Way
Markham Vale
Chesterfield
Derbyshire
S44 5JX
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
23. Oktober 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
29. August 2024
FB Adresse C/O Marlowe Plc
London
SW1X 7HN
Firmenbuch-Nummer 10345605 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)36000 - Wasserversorgung
46750 - Großhandel mit chemischen Erzeugnissen
74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
77320 - Vermietung von Baumaschinen und –geräten
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Marlowe 2016 Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2023 Companies House Nummer: 09975667 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Hamilton, Blair William Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2016 Löschung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 10.1951 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mobile & Separation Equipment Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2016 Löschung: 01.04.2021 Companies House Nummer: 04194135 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Wcs Environmental Engineering Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2021 Löschung: 28.06.2023 Companies House Nummer: 02583411 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Bone, Christopher London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Rolle: Secretary
    Councell, Adam Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2021 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hitchcock, Jamie Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Walls, Andrew Raymond Quedgeley, Gloucester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Allen, Matthew James London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2021 Löschung: 01.08.2023 Rolle: Secretary
    Dacre, Alexander Peter London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2021 Löschung: 22.05.2024 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Greenwood, Philip Edwin Quedgeley, Gloucester, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2021 Löschung: 16.11.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British