USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Restore Technology Limited

Adresse
Cardington Point
Telford Way
Bedford
MK42 0PQ
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 04200502 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)39000 - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • IT Efficient Limited
  • P C Efficient Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Restore Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2020 Companies House Nummer: 13052690 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Restore Plc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.12.2020 Companies House Nummer: 05169780 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors as firm
  • Significant influence or control as firm
  • Officers (12)

    Quelle: Companies House
    Baker, Daniel John London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Chotai, Uxsheay Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Fussell, Christopher London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Rolle: Secretary
    Hulmes, Iain Mcphee Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Jackson, Quentin Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Skinner, Charles Antony Lawrence London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Gooding, Duncan Charles Bedford, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2022 Löschung: 15.10.2023 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hopkins, Jameson Paul London, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.08.2023 Löschung: 15.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Killick, Michael David London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2023 Löschung: 13.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Ritchie, Neil James London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2019 Löschung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Talbot, Stephen Richard Bedford, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2023 Löschung: 14.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Valbonesi, Penelope Jane Bedford, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2021 Löschung: 18.08.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

    gb-flag Computer Disposals Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2021 Companies House Nummer: 04033271 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB MAC2Cash LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Companies House Nummer: 09433434 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Spinnaker Waste Management LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2018 Companies House Nummer: 06992571 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag The Bookyard LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Companies House Nummer: 05875844 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Ultratec (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2022 Companies House Nummer: 08603012 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB € Recycling Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2020 Companies House Nummer: 04528854 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors