USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Arrow Valley Management Company (NO.1) Limited

Adresse
6th Floor
65 Gresham Street
London
EC2V 7NQ
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 05241044 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussdormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Aberdeen City Council Acting As The Administering Authority For Aberdeen City Council Pension Fund Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2016 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Calthorpe Edgbaston Mill Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2016 Companies House Nummer: 05648676 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Urban Logistics Acquisitions 8 Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2023 Companies House Nummer: 13767118 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Bnp Paribas S.A. Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.01.2023 Companies House Nummer: Fr0000131104 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Cip Threadneedle Uk Property Nominee No.1 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.07.2016 Companies House Nummer: 05444253 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Cip Threadneedle Uk Property Nominee No.2 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.07.2016 Companies House Nummer: 05444256 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Equity Partnerships (Osprey) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.05.2016 Companies House Nummer: 04299729 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Threadneedle Asset Management Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.01.2023 Companies House Nummer: 03554212 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • gb-flag GB Threadneedle Portfolio Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.01.2023 Companies House Nummer: 00285988 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control as trust
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Hall, Nicola Jane London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2023 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    gb-flag GB Link Company Matters Limited 29 Wellington Street, Leeds, United Kingdom, LS1 4DL Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2013 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05306796
    Link Company Matters Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British
    Turner, Christopher David Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2023 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Wooldridge, David Ian Edgbaston, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2021 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English
    Campbell, Nicola Edinburgh, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 25.03.2019 Löschung: 10.10.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Shattock, Nicholas Simon Keith Dulwich, London Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2004 Löschung: 20.12.2010 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Thompson, Duncan Edward London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2015 Löschung: 12.01.2023 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British