USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Healthier Tastier Food LTD

Adresse
Unit 15, Muirhead Quay
Freshwharf Highbridge Road
Barking
IG11 7BG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
15. Jänner 2023
FB Adresse Sussex Innovation 12-16 Addiscombe Road
London
CR0 0XT
Firmenbuch-Nummer 13039304 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussmicro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
FB Statusadministration
Vorherige Namen
  • Keep IN Business Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Jadenfinch Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2023 Companies House Nummer: 10645403 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as firm
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Voting rights 25 to 50 percent as firm
  • gb-flag GB Jph Investments 2022 Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2023 Companies House Nummer: 14073111 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as firm
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Tolladine Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2023 Companies House Nummer: 03106864 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as firm
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Voting rights 25 to 50 percent as firm
  • Burrows, Timothy John Status: Inaktiv Eintragung: 24.11.2020 Löschung: 24.01.2023 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Kasapis, Chrisostomos Wimbledon, Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Collins, Jason Wimbledon, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2023 Löschung: 11.09.2023 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pollard, William Michael Wimbledon, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2023 Löschung: 11.09.2023 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Scales, John Robert Wimbledon, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2023 Löschung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Warne, James Richard Wimbledon, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2023 Löschung: 22.05.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

    gb-flag GB Diamond Catering Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Companies House Nummer: 04383172 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Healthier Tastier Food Cornhill LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2023 Companies House Nummer: 14654430 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Healthier Tastier Food Cornhill LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2023 Companies House Nummer: 14654430 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors