USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Suez Recycling and Recovery UK LTD

Adresse
Units 301-303 Parkway
Worle
Weston Super Mare
North Somerset
BS22 6WA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
2. Juli 2016
FB Adresse Suez House
Maidenhead
SL6 1ES
Firmenbuch-Nummer 02291198 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)38110 - Sammlung nicht gefährlicher Abfälle
38210 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle
38320 - Rückgewinnung sortierter Werkstoffe
39000 - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Suez Recycling and Recovery UK LTD | Suez R & R
  • Suez Recycling and Recovery UK LTD | Suez R&R UK
  • Suez Recycling and Recovery UK LTD Suez R&R UK
  • Sita UK Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Suez Recycling And Recovery Holdings Uk Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03475737 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Mayson, Gary Maidenhead, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Scanlon, John James Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2009 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish
    Thompson, Mark Hedley Maidenhead, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2009 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Head Of Legal And Comapny Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British
    Thorn, Christopher Derrick Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Palmer-Jones, David Courtenay Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2008 Löschung: 01.01.2020 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB DCW Holdco LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2023 Companies House Nummer: 14739652 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag F & R Cawley LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Companies House Nummer: 04170234 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Midland Land Reclamation Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01691901 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Shropshire Waste Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02627501 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Shukco 2020 LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2020 Companies House Nummer: 12455931 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Shukco 341 LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02937394 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Suez Connect UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2019 Companies House Nummer: 12192400 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Suez Recycling and Recovery Suffolk LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07346155 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Suez Recycling and Recovery Suffolk LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07346155 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Suez Recycling and Recovery Surrey LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03184332 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors

  • Branch VAT Numbers (1)

    gb-flag Browning Ferris Services LTD5 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middx, UB11 1BX