USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

TAG Systems UK Limited

Adresse
2 Cecilia Road
Hackney
London
E8 2EP
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
14. August 2017
FB Adresse 32 Marathon Place
Leyland
PR26 7QN
Firmenbuch-Nummer 03215488 Companies House Eintrag ansehen
FB Status aktiv
Gründungsdatum24. Juni 1996
JahresabschlussFULL
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)17230 - Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe
22290 - Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren
82920 - Abfüllen und Verpacken
Vorherige Namen
  • Nitecrest Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    Hart (Deceased), Executors Of Ronald Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 11.1940 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Hart, Ronald Michael Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2021 Löschung: 20.12.2021 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Hart, Ronald Michael Leyland, Preston, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2001 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kirchmayr, Markus Moss Side Industrial Estate, Leyland, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2021 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: Austrian
    Kontos, Emmanouil Leyland, Preston, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: Greek
    Neeras, Jon Moss Side Industrial Estate, Leyland, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2021 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Norway Nationalität: Norwegian
    Pye, Leeroy Leyland, Preston, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2010 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Spyropoulos, Panagiotis Moss Side Industrial Estate, Leyland Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2021 Löschung: 28.03.2024 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

    gb-flag TAG Nitecrest Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09892954 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB First Class Response Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.09.2021 Companies House Nummer: 03247686 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Nitecrest Digital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2018 Löschung: 06.09.2021 Companies House Nummer: 11247520 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more