USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Starlight Science Limited

Adresse
3rd Floor
1 Red Place
London
W1K 6PL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
6. Februar 2023
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
12. August 2024
FB Adresse Gdc First Avenue
Deeside
CH5 2NU
Firmenbuch-Nummer 14419310 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary

Branche (ÖNACE)72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Convatec Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Companies House Nummer: 01309639 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Chan, Adriel Wenbwo Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2023 Löschung: 18.04.2023 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Convatec Inc. Status: Inaktiv Eintragung: 18.04.2023 Löschung: 30.06.2023 Companies House Nummer: 04550595 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Hanna, Wilfred Sydney Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2022 Löschung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Wong, Yuk Lan Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2023 Löschung: 18.04.2023 Geburtsdatum: 03.1967 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Mccalla, Grace 23 Forbury Road, Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2023 Rolle: Secretary
    Patankar, Vivek Vikas 23 Forbury Road, Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2023 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Vice President Awc Global Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Shepherd, David Richard 23 Forbury Road, Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2023 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: President And Coo Advanced Woundcare Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Vicinanza, Gregg Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2023 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Vice President, Deputy General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Willis, Sean Leo Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2023 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Vice President R&d Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British