USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Cocksedge Building Contractors Limited

Adresse
25 Hampstead Avenue
Mildenhall
Bury St. Edmunds
IP28 7AS
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 04007482 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
41201 - Bau von Gebäuden
41202 - Bau von Gebäuden
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Cocksedge (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05573035 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Ashworth, Mark Anthony Bury St Edmunds, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Pre-Construction Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Buckingham, Justin Peter Mildenhall, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2014 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Contract Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Gee, Graham Colin Suffolk Business Park, Bury St Edmunds, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Nugent, Stephen Christopher Lakenheath, Brandon, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2005 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Quantity Surveyor Contracts Ma Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Reeve, Darren John Mildenhall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wood, Nigel Robert Lionel Bury St Edmunds, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Grant, Timothy Andrew Mildenhall, Bury St. Edmunds Status: Inaktiv Eintragung: 19.05.2011 Löschung: 09.08.2024 Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag ABS Build Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2021 Companies House Nummer: 13520431 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Breck Gardens LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2022 Companies House Nummer: 11370716 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag Burlingham Mill Partnership LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Companies House Nummer: 14524977 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Burnham Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Companies House Nummer: 12200851 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag Histon Station Development LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2018 Companies House Nummer: 11706140 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag Humberstone Road Developments LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2016 Companies House Nummer: 10166943 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Right to appoint and remove directors as firm
  • Significant influence or control as firm
  • gb-flag GB Icknield WAY Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2018 Companies House Nummer: 11662367 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lakenheath Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2023 Companies House Nummer: 14790400 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Breck Gardens Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2020 Löschung: 01.09.2022 Companies House Nummer: 12929699 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Histon Station Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.10.2020 Löschung: 08.03.2023 Companies House Nummer: 12942300 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors