USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Europort Properties LTD

Adresse
Altofts Lane
Castleford
WF10 5PZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
17. April 2023
FB Adresse 6th Floor 125 London Wall
Castleford
EC2Y 5AS
Firmenbuch-Nummer 14127961 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full

Branche (ÖNACE)68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Europort Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Viamaster Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2023 Löschung: 13.03.2023 Companies House Nummer: 14459460 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Warrington, Andrew Bernard Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2022 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 05.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Warrington, David Kevin Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2022 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Apex Financial Services (secretaries) Limited 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 00058502
    Golebiowski, Adam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swiss
    Lelli, Luca London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2024 Beschäftigung: Company Director/executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian
    Minson, Gregory Paul, Mr. London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Warrington, Andrew Bernard Guiseley, Leeds Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Kilbey, Nick Castleford, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2024 Löschung: 23.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Warrington, Andrew Bernard Guiseley, Leeds Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2022 Löschung: 09.08.2024 Rolle: Secretary
    Warrington, David Kevin Pudsey Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2022 Löschung: 09.08.2024 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag Viamaster Transport Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2022 Löschung: 22.02.2023 Companies House Nummer: 01011790 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors