USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Curtis Banks Limited

Adresse
3 Temple Quay
Bristol
BS1 6DZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
FB Adresse Dunn's House
Bristol
SP2 7BF
Firmenbuch-Nummer 06758825 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)65300 - Pensionskassen und Pensionsfonds
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Banks Pensions PLC
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Curtis Banks Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07934492 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (12)

    Quelle: Companies House
    Bruce, Michelle Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Rolle: Secretary
    Clarkson, Alastair James Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2022 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Docherty, Peter Gordon John Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hoskins, Richard Temple Back East, Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Regan, Michael Robert Temple Back East, Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Riley, Cathryn Elizabeth Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Cowland, Dan James Ipswich, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2019 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Curtis, Rupert Morris Temple Back East, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2009 Löschung: 31.12.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Davidson, Judith Mary Temple Back East, Salisbury, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2023 Löschung: 01.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Millard, Gemma Louise Salisbury, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2015 Löschung: 29.02.2024 Rolle: Secretary
    Presley, Nicola Marie Temple Back East, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2013 Löschung: 20.07.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Purves, Kathryn Elizabeth Temple Back East, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2023 Löschung: 20.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Bridgewater Pension Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03821053 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB CB 2019 Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2016 Companies House Nummer: 07020940 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Colston Trustees LTD | Curtis Banks Sipp 101337 WFS Payne. Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06867955 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Crescent Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03915165 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB SPS Trustees LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08312411 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Temple Quay Pension Trustees LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05679427 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Tower Pension Trustees LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02178783 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Tower Pension Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02178783 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Tower Pension Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02178783 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Waymade Healthcare Scheme Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2016 Löschung: 27.09.2017 Companies House Nummer: 07103725 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more