USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Shoreditch Village Limited

Adresse
Hill Farm Barn
Bruern Road
Milton-Under-Wychwood
Chipping Norton
OX7 6HB
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
FB Name Shoreditch Village LTD
FB Adresse 28 Church Road
Stanmore
HA7 4XR
Firmenbuch-Nummer 01446901 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Shoreditch Village Holdings Limited
  • Lirastar Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

    Quelle: Companies House
    Clarkson, John Francis Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 07.1944 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Hall, Andrew Edward Valentine Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Messrs Hoare Trustees Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Companies House Nummer: Zc000159 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • White, Anthony Johnstone Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 12.1939 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • White, Roxana Janet Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 12.1943 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Hall, William George Valentine Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2016 Löschung: 25.04.2019 Geburtsdatum: 06.1939 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (3)

    Quelle: Companies House
    Hall, Andrew Edward Valentine Wimbledon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.1991 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    White, Dominic Henry Johnstone Bruern Road Milton-Under-Wychwood, Chipping Norton, Oxfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.1991 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    White, Jonathan Bernard Johnstone Stanmore, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1994 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Marketing Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag GB Shoreditch Village Hotel LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2016 Companies House Nummer: 08830999 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Shoreditch Village Residential LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2016 Companies House Nummer: 08831003 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors