USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

European Investments (Cornwall)Limited

Adresse
Egg Farm Lane Off Station
Road Kings Langley
Hertfordshire
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
10. Mai 2016
Firmenbuch-Nummer 08030338 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB European Investments (Scel) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08022435 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (11)

    Quelle: Companies House
    Andrews, Stewart James Kings Langley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Commercial Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cotton, Richie John Kings Langley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2025 Beschäftigung: Senior Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Crawford, John Kings Langley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Commercial Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Scottish
    Hearth, Dominic Kings Langley, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2013 Rolle: Secretary
    Martina, Giorgia Off Station Road, Kings Langley Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2020 Geburtsdatum: 04.1985 Beschäftigung: Investment Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian
    Scott, Tracy Jane Off Station Road, Kings Langley, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2018 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Delivery Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Campbell, Alasdair Kings Langley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2024 Löschung: 19.11.2024 Beschäftigung: Investment Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hoddell, Laura Elspeth Off Station Road, Kings Langley Status: Inaktiv Eintragung: 30.12.2019 Löschung: 26.02.2025 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Senior Trig Commercial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British
    Hughes, Steven William Off Station Road, Kings Langley Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2018 Löschung: 28.11.2019 Beschäftigung: Global Support Services Director, Uk&i - Commercia Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kingsley, Louise Charlotte Hetty Off Station Road, Kings Langley Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2022 Löschung: 06.05.2024 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Legal Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mcerlane, Andrew John Kings Langley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2024 Löschung: 24.05.2024 Beschäftigung: Asset Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

    gb-flag GB Churchtown Farm Solar Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07611290 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB East Langford Solar Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07610799 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Manor Farm Solar Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07611300 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors