USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Mortgage and Surveying Servi CES Limited

Adresse
3-4 Regan Way
Chetwynd Business Park
Chilwell
Nottingham
NG9 6RZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
16. März 2019
FB Name Mortgage and Surveying Services Limited
Firmenbuch-Nummer 06055271 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Shepherd Direct Limited
  • SDL Property Services Group Limited | SDL Group
  • SDL Property Services Group Limited
  • Castlegate 464 Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Bgf Investment Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Companies House Nummer: 10608481 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Bgf Gp Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2017 Löschung: 01.05.2023 Companies House Nummer: 10657217 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Business Growth Fund Plc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.10.2017 Companies House Nummer: 07514847 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB J&E Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.05.2017 Companies House Nummer: Sc237007 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (13)

    Quelle: Companies House
    Brewster, George Pattullo Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2007 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Clifford, Robert Martin Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2014 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gratton, Elizabeth Anne Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gratton, Paul Robert Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2007 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hickling, Christopher Charles Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2014 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hickling, Julia Ann Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jackson, Simon Paul Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Tuck, Sarah Kate Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Rolle: Secretary
    Walker, Heath Lee Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Warriner, Stuart Neil Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Chair Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Williams, Jill Caroline Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Investor Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Anderton, Colin James Chetwynd Business Park Chilwell, Nottingham Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2020 Löschung: 27.07.2020 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fergusson, Ian James Stirling Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2007 Löschung: 11.07.2014 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Director, Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Connect IFA LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2022 Companies House Nummer: 05501124 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Curve Conveyancing Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2024 Companies House Nummer: 15639604 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Stonebridge Mortgage Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2018 Companies House Nummer: 05601592 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB GLF Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2017 Löschung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 10663506 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Graham Penny Auctions LTD | Graham Penny Auctions Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 06422992 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB SDL Auctions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 07719474 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag SDL Group Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2017 Löschung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 10663384 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag SDL Group Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2017 Löschung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 10663384 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag SDL Group Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2017 Löschung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 10663384 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag WL Estate Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2020 Löschung: 04.12.2020 Companies House Nummer: 12673845 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors