USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

JBG Holdings LTD

Adresse
35 Church Road
Fleet
Hampshire
GU51 4NA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
1. Oktober 2017
FB Name JBG Holdings Limited
FB Adresse 28 Prescott Street
Halifax
HX1 2JL
Firmenbuch-Nummer 06866012 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • JBG Holdings Limited | Cash Converters
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    Cox, Ben Walter Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Cox, Gordon Walter Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1949 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Cox, Janet Mary Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Spratley, James Peter Conway Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.08.2021 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (3)

    Quelle: Companies House
    Cox, Ben Walter Halifax, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2009 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cox, Joe Thomas Halifax, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2022 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Spratley, James Peter Fleet, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2021 Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

    gb-flag Cash Converters (Shipley) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07077724 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Cash Converters FS Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07267720 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Cash Converters Lancashire Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04716309 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Cash Converters North East Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07577496 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Cash Converters Yorkshire Limited | Cash Converters Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06347684 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag JBG Investment Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2020 Companies House Nummer: 12525532 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more