USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Geschäftsname

UK Plumbing Supplies Limited

Handelsname Thame Plumbing Supplies
Adresse
17 Worcester Road
Trade Park
Chipping Norton
Oxon
OX7 5XW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
9. November 2019
FB Name UK Plumbing Supplies Limited
FB Adresse Quayside 2a Wilderspool Park
Stockton Heath
WA4 6HL
Firmenbuch-Nummer 02723962 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)46740 - Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Plumbing and Heating Investments Limited
  • Marlowe Investments Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Marlowe Holdings Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00462411 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Christie, Douglas Brash Greenalls Avenue, Stockton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Christie, Douglas Brash Greenalls Avenue, Stockton Heath, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Rolle: Secretary
    Falconer, Angus Kenneth Knutsford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hogg, Anthony Greenalls Avenue, Stockton Heath, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 12.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Love, Gordon Alexander Greenalls Avenue, Stockton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mcnair, Douglas Talbot Greenalls Avenue, Stockton Heath, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 06.08.1992 Geburtsdatum: 08.1947 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wimbledon, Steven John Whitehall Industrial Estate, Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Woof, William Sones Greenalls Avenue, Stockton Heath, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2017 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag AMS Plumbers Merchants Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2023 Companies House Nummer: 11712298 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Bathroom Centre Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Companies House Nummer: 07229565 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Bathroom Centre Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Companies House Nummer: 07229565 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB GAS Centre Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Companies House Nummer: 11662042 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Maymask (249) Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Companies House Nummer: 15340604 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Millbrook Distribution and Spares Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2019 Companies House Nummer: 03241583 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Plumbcity Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2016 Companies House Nummer: 04477777 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Plumbing and Heating Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Companies House Nummer: 05343940 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Plumbstop Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2017 Companies House Nummer: 02666030 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors