USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Coyote Ugly London Limited

Adresse
30 Shaftesbury Avenue
London
W1D 6EX
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
2. April 2023
FB Adresse 100 St. James Road
Bristol
NN5 5LF
Firmenbuch-Nummer 13569697 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussdormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56302 - Ausschank von Getränken
FB Statusliquidation
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Alexa Luxury Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2022 Companies House Nummer: 12731191 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Breaking Brands International Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2022 Löschung: 08.06.2023 Companies House Nummer: 13509797 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Bw Investment Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2022 Löschung: 20.12.2022 Companies House Nummer: 14042296 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Lewis, Steve John Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2021 Löschung: 20.12.2022 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Taplin, Nicholas James Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2021 Löschung: 30.08.2022 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Hadeed, Hassan Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.12.2022 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lewis, Steve John Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2021 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British
    Livingston, Justin Reynolds Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2022 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Franchise Development/consulting Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    O'Neil, David John Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2022 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Taplin, Nicholas James Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2021 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wilce, Caroline Jayne Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2022 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Young, Christopher Ian Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2022 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British