USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Onpath Energy Limited

Adresse
Chase House
4 Mandarin Road
Houghton Le Spring
DH4 5RA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
7. April 2019
Firmenbuch-Nummer 02387216 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)35110 - Elektrizitätserzeugung
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Banks Renewables Limited
  • Gilbert Gray Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Brookfield Corporation Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Companies House Nummer: 01644037 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Onpath Energy Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Companies House Nummer: 00150156 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Banks Renewables Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2018 Löschung: 14.12.2023 Companies House Nummer: 11269789 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB The Banks Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2018 Companies House Nummer: 02267400 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Timec 1638 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2018 Löschung: 27.07.2018 Companies House Nummer: 11269789 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Dunkley, Richard John Houghton-Le-Spring, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2009 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fisher, Andrew Simon David Houghton-Le-Spring, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2015 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wright, Ashley John Houghton-Le-Spring, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2024 Rolle: Secretary
    Banks, Harry James Meadowfield, Durham, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.1992 Löschung: 14.12.2023 Geburtsdatum: 11.1940 Beschäftigung: Group Chairman And Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gill, Christopher John Meadowfield, Durham Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2022 Löschung: 14.12.2023 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Martin, David Joseph Houghton-Le-Spring, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.1992 Löschung: 07.06.2024 Geburtsdatum: 11.1957 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Banks Renewables (Birneyknowe Wind Farm) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06903043 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Banks Renewables (Sauchanwood Hill Wind Farm) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08464595 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Camvo 201 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08843252 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Gravis Onshore Wind 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2025 Companies House Nummer: 10978700 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Armistead Wind Farm Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.07.2018 Companies House Nummer: 06263761 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Hook Moor Wind Farm Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2018 Companies House Nummer: 06111462 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Kype Muir Wind Farm Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.11.2016 Companies House Nummer: 06917667 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Lambs Hill Wind Farm Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2018 Companies House Nummer: 06798765 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Penny Hill Wind Farm Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.05.2016 Companies House Nummer: 06521870 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Thorpe Marsh Green Energy HUB Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2022 Löschung: 24.08.2023 Companies House Nummer: 14403918 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors