USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Willow Pumps Limited

Adresse
Willow Pumps Ltd
Hall Park Farm
Hall Road
Aylesford
ME20 7QZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
15. Mai 2019
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
14. Februar 2020
Firmenbuch-Nummer 02762063 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Wpl Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Companies House Nummer: 10802100 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Hemsley, Stephen Glen Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2019 Löschung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Lawrence, Ian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.11.2017 Geburtsdatum: 05.1960 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Lawrence, Suzanne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.11.2017 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Wpl Group Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2017 Löschung: 07.10.2019 Companies House Nummer: 10802100 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Wray, Nigel William Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2019 Löschung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 04.1948 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Mallows, Andrew John Tytherington Business Park, Macclesfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British
    Molloy, Peter John Tytherington Business Park, Macclesfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2019 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Peace, Bethany Rose Tytherington Business Park, Macclesfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Perry, Kevin Michael Tytherington Business Park, Macclesfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wicks, Christopher Thomas Tytherington Business Park, Macclesfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hemsley, Stephen Glen Tytherington Business Park, Macclesfield, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 20.11.2023 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Chair Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lawrence, Ian Forge Lane High Halstow, Rochester Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.1992 Löschung: 30.08.2023 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag GB MRB Drainage Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2019 Companies House Nummer: 06809970 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB MRE Drainage Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Companies House Nummer: 11179211 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more