USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Nuffield Health

Adresse
2 Ashley Avenue
Epsom
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
4. Dezember 2020
FB Adresse Epsom Gateway
Epsom
KT18 5AL
Firmenbuch-Nummer 00576970 Companies House Eintrag ansehen
FB Status aktiv
Gründungsdatum14. Jänner 1957
JahresabschlussGROUP
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
Vorherige Namen
  • Nuffield Hospitals
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Officers (12)

    Quelle: Companies House
    Bajwa, Junaid Azmat Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Figgis, Patrick Adam Fernesley Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2018 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Killen, Tracey Anne Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2023 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Macdonald, Natalie-Jane Anne Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2017 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Scottish
    Maslin, Stephen Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2017 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Robb, Elizabeth Jane Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Rochford, Lee Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Sachdev, Nilesh Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2018 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Stansfeld, Mark Andrew Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Thomson, Iben Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Rolle: Secretary
    Whitworth, Karen Tracy Epsom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Adebowale, Victor Olufemi, Lord Epsom Status: Inaktiv Eintragung: 26.06.2019 Löschung: 18.10.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Bladerunner Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04035973 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Chichester Independent Hospital Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02542995 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Greens Health and Fitness Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06126413 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Healthscore LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08609624 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Independent Surgery Centres Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03004585 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Jonathan Webb Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04605061 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mythbreaker Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05581441 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Nuffield Health ONE Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2018 Companies House Nummer: 11171870 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Nuffield Health Pension Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 10001741 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Vale Health Partners Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06023923 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors