USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Threadneedle Asset Management Holdings LTD

Adresse
Cannon Place
78 Cannon Street
London
EC4N 6AG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
11. April 2017
FB Name Threadneedle Asset Management Holdings Limited
Firmenbuch-Nummer 03554212 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Tam Uk Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06779814 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Bennett, Elliot James London Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2023 Beschäftigung: Senior Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fisher, Michael Thomas London Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kaye, Alan London Status: Aktiv Eintragung: 26.11.1999 Geburtsdatum: 09.1951 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Perrin, James William London Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Burgess, Mark Andrew London Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2011 Löschung: 27.09.2019 Beschäftigung: Chief Investment Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Logan, David London, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2022 Löschung: 18.12.2023 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Ring, Nicholas John London Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2019 Löschung: 22.11.2023 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag GB Airport City (Asset Manager) Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2020 Companies House Nummer: 08723467 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag Airport City (General Partner) LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2020 Companies House Nummer: 08723477 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Hadrian East Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2018 Companies House Nummer: 03341463 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • gb-flag Threadneedle Curtis Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2020 Companies House Nummer: 04330721 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as firm
  • Voting rights 75 to 100 percent as firm
  • Right to appoint and remove directors as firm
  • gb-flag GB Salbrook Road Management Company NO. 1 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2018 Löschung: 28.03.2024 Companies House Nummer: 06282821 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • gb-flag GB Salbrook Road Management Company NO. 2 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2018 Löschung: 28.03.2024 Companies House Nummer: 06282823 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • gb-flag GB The Millennium Centre (Farnham) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2018 Löschung: 21.02.2023 Companies House Nummer: 03549341 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Significant influence or control as trust
  • gb-flag Uxbridge Business Park Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2018 Löschung: 29.07.2022 Companies House Nummer: 02451879 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • gb-flag GB Warley Hill Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2018 Löschung: 27.01.2023 Companies House Nummer: 02744200 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 50 to 75 percent as trust
  • Voting rights 50 to 75 percent as trust
  • Significant influence or control as trust