USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Skratch Enterprises Limited

Adresse
Unit 37-38
Ketley Business Park
Ketley
Telford
TF1 5JD
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
29. Mai 2018
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
19. April 2024
FB Adresse C/O Mincoffs Solicitors Llp, 5 Osborne Terrace
Newcastle Upon Tyne
NE2 1SQ
Firmenbuch-Nummer 05050095 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 20. Juni 2022
Branche (ÖNACE)43290 - Sonstige Bauinstallation
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Jaetec Limited
  • Jaetec Engineering Solutions Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB L.B. Foster Rail Technologies (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Companies House Nummer: 03939427 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Skratch Corporation Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2019 Löschung: 21.06.2022 Companies House Nummer: 11872065 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Walsh, Rebecca Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Walsh, Stephen James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Boura, Emma Patricia Jesmond, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kelly, Brian Hague Jesmond, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2024 Beschäftigung: Human Resources Executive Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Reilly, Sean Jesmond, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Corporate Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Sheffield, Neil Jason Jesmond, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jones, Peter David Vaughan Jesmond, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2022 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kasel, John Francis Jesmond, Newcastle Upon Tyne, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2022 Löschung: 30.01.2024 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Roberts, Suzanne Jesmond, Newcastle Upon Tyne, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2022 Löschung: 28.03.2024 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British