USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

GJP Dunwoody LTD

Adresse
Telford Court Nursing Home
Cheshire
Crewe
CW1 3AW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
16. Juni 2017
FB Name GJP Dunwoody Limited
Firmenbuch-Nummer 07049571 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Keenrick Care Homes Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Inspired Life Care Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2019 Companies House Nummer: 10561246 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Amantius Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2017 Löschung: 12.03.2019 Companies House Nummer: 05837607 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Chawner, Rupert Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.05.2017 Geburtsdatum: 04.1943 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Geohn Developments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2017 Löschung: 12.03.2019 Companies House Nummer: 08902298 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Scp Dunwoody Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2017 Löschung: 12.03.2019 Companies House Nummer: 10505704 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (3)

    Quelle: Companies House
    Chawner, Lucy Melissa Llandudno, Conwy, Wales Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2019 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Chawner, Rupert Christopher Llandudno, Conwy, Wales Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2019 Geburtsdatum: 04.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Graham, Colin William Edward Farnworth, Bolton, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2017 Löschung: 25.01.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British