USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

CC Stim UK Holdco LTD

Adresse
18 Linford Forum
Rockingham Drive
Linford Wood
Milton Keynes
MK14 6LY
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
14. September 2022
Firmenbuch-Nummer 13067085 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Cc Stim Uk Topco Ltd Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Companies House Nummer: 13066237 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (3)

    Quelle: Companies House
    Falbert, Adam Nederby Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish
    Hahn-Petersen, Vilhelm Eigil Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish
    Marks, Peter Jack Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2021 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag CC Stim UK Tradeco 3 LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Companies House Nummer: 13068680 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag CC Stim UK Tradeco 3 LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Companies House Nummer: 13068680 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag CC Stim UK Tradeco 4 LTD Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Companies House Nummer: 13073929 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag CC Stim UK Tradeco 5 LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2021 Companies House Nummer: 13258800 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag CC Stim UK Tradeco 6 LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2021 Companies House Nummer: 13312771 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag CC Stim UK Tradeco 6 LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2021 Companies House Nummer: 13312771 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Neos 15 LTD Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2021 Löschung: 01.02.2024 Companies House Nummer: 13322304 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Neos 17 LTD Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2022 Löschung: 01.02.2024 Companies House Nummer: 14267541 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Neos 21 LTD Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2022 Löschung: 01.02.2024 Companies House Nummer: 14267914 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Neos SPV 1 LTD Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2021 Löschung: 01.02.2024 Companies House Nummer: 13322203 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors