USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Amkeu Limited

Adresse
174 Hammersmith Road
London
Greater London
W6 7JP
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
10. Februar 2020
FB Name Products Dormant CO 2 Limited
FB Adresse 298 Marlborough House
London
N3 2SZ
Firmenbuch-Nummer 10261807 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)10890 - Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Amkeu Limited | Nooro
  • Nooro Limited
  • Market Food Provider LTD
  • Partisan Foods LTD
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Nooro Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Companies House Nummer: 12142171 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • gb-flag GB Ech Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2018 Löschung: 02.10.2019 Companies House Nummer: 11245294 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • Furlong, John-David Status: Inaktiv Eintragung: 05.07.2016 Löschung: 08.11.2018 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Nooro Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2020 Löschung: 31.07.2020 Companies House Nummer: 12142171 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • gb-flag GB Partisan Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2018 Löschung: 31.07.2020 Companies House Nummer: 05888136 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (3)

    Quelle: Companies House
    Furlong, John David Regents Park Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2016 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish
    Murphy, Stephen London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2019 Löschung: 29.08.2019 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish
    Nadler, Jonathan David London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2018 Löschung: 10.09.2020 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

    gb-flag GB Products Dormant CO 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Companies House Nummer: 12142176 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Budca LTD Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2018 Löschung: 31.12.2019 Companies House Nummer: 11204334 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Products Dormant CO 2 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2019 Löschung: 31.07.2020 Companies House Nummer: 11693000 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more