USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Container Components Europe Limited

Adresse
Hm Revenue And Customs
Ruby House
8 Ruby Place
Aberdeen
AB10 1ZP
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Juli 2023
FB Adresse Oak Park Ryelands Lane
Chesterfield
WR9 0QZ
Firmenbuch-Nummer 02958511 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)22290 - Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Egbert Taylor Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2022 Companies House Nummer: 11064970 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors
  • Taylor, Craig Valentine Status: Inaktiv Eintragung: 11.08.2016 Löschung: 23.06.2022 Geburtsdatum: 11.1939 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Allen, Hunter Holmewood Industrial Park, Chesterfield Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2022 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Blythe, Nicholas Mark Holmewood Industrial Park, Chesterfield Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2008 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Bull, Lisa Rebecca Elmley Lovett, Droitwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Moore, Michael Anthony Elmley Lovett, Droitwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Powell, Lisa Rebecca Holmewood Industrial Park, Chesterfield Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2022 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Richmond, Kenneth Roy Elmley Lovett, Droitwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2007 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Williams, David John Elmley Lovett, Droitwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Braddock, Michael James Elmley Lovett, Droitwich, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2023 Löschung: 26.01.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Murphy, Brendan Francis Elmley Lovett, Droitwich, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2022 Löschung: 21.12.2023 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British