USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

International Management Group (UK) LTD

Adresse
Building 6, Chiswick Park
566 Chiswick High Road
London
W4 5HR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
FB Name International Management Group (UK) Limited
Firmenbuch-Nummer 00946580 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
93110 - Betrieb von Sportanlagen
93120 - Sportvereine
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Endeavor Group Holdings, Inc. Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2023 Companies House Nummer: 07135118 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Emanuel, Ariel Zev Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Whitesell, Patrick William Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Cooper, John Atlanta, Georgia, United States Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2016 Rolle: Secretary
    Cooper, John Thomas Atlanta, Georgia, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2018 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Maglione, Bruno Walter Burlington Lane Chiswick, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2012 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American
    Matharu, Anil Singh 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hayllar, Nicholas James London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2017 Löschung: 31.08.2018 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

    gb-flag GB BSI Speedway (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05713374 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag Clifford French LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2018 Companies House Nummer: 06508692 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB P W R Events Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03827071 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Quintus Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04677826 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Taste Festivals Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05010667 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag European Golf Design LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.01.2021 Companies House Nummer: 02425622 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

  • Branch VAT Numbers (1)

    gb-flag Marksmen International (Management Overseas) LTDThe Pier House, Strand On The Green, Chiswick, London, W4 3NN