USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

G A E Smith (Holdings) LTD

Adresse
Feldspar Close
Warren Industrial Park
Enderby
Leicester
LE19 4SD
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
5. April 2023
FB Name G.A.E. Smith (Holdings) Limited
FB Adresse Kelsall House
Telford
TF3 3BD
Firmenbuch-Nummer 01075198 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)38110 - Sammlung nicht gefährlicher Abfälle
38320 - Rückgewinnung sortierter Werkstoffe
39000 - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
46770 - Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Gae Smith Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2021 Companies House Nummer: 13515578 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Corser, Corinne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.06.2018 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • gb-flag GB Oceala Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.07.2021 Companies House Nummer: 01669351 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Smith, Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.06.2018 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Smith, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.06.2018 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Woolley, Maxine Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.06.2018 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Cox, Paul Anthony Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2021 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cullen, Georgina Warren Industrial Park, Enderby Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2009 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Purchasing Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Smith, Mark Warren Industrial Park, Enderby, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.1991 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sullivan, John Terence Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2021 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sullivan, John Terrence Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2021 Rolle: Secretary
    Wakeley, Guy Richard Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag GB Casepak Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00982279 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Cleanwrap Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01086079 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more