USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Tilia Homes Limited

Adresse
Tungsten
Central Boulevard
Blythe Valley Park Shirley
Solihull
B90 8AU
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
15. Mai 2016
Firmenbuch-Nummer 00775505 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)41202 - Bau von Gebäuden
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Kier Living Limited
  • Kier Homes Limited
  • Kier Residential Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    Hands, Guy Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Kier Group Plc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.05.2021 Companies House Nummer: 02708030 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Chapman, Philip Andrew Solihull, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Dilley, Mark John Solihull, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2021 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Gibbs, Alexander Solihull, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gibbs, Alexander, Mr. Solihull, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hammond, Andrew Richard Solihull, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Wilson, Daniel Stewart Solihull, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2022 Rolle: Secretary
    Bharadwaj, Ishan Manchester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2021 Löschung: 06.05.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Browne, Daniel Harry Rate Sandy Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2010 Löschung: 31.01.2017 Beschäftigung: Land Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Coker, Michael John Manchester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2020 Löschung: 04.02.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Allison Homes Eastern Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04280860 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Alston Grange Preston Road Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2019 Companies House Nummer: 12063005 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Alston Grange Preston Road Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2019 Companies House Nummer: 12063005 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Gateway 2 Ashton Green Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2024 Companies House Nummer: 15457199 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Grendon Point ( Atherstone) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Companies House Nummer: 12535291 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Landimore Park (Hardingstone) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Companies House Nummer: 13488392 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Roundhouse Gate (Cringleford) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2020 Companies House Nummer: 12409010 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB SEA Place Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2023 Companies House Nummer: 06977171 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Stortford Fields 2 (Bishop Stortford) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2024 Companies House Nummer: 15392809 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Tilia Living Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2020 Companies House Nummer: 12600894 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors

  • Branch VAT Numbers (1)

    gb-flag Denson Developments LTDThe Shrubbery, Church Street, St Neots, Huntington, Cams, PE19 2BU