USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Aura (Newcastle) Project Company Phase 2 LTD

Adresse
1 Park Row
Leeds
LS1 5AB
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 07033324 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Aura (Newcastle) Holding Company Phase 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07033345 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Davies, Howard Robert St James' Boulevard, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gordon, John Stephen 19a Canning Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2015 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Infrastructure Managers Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British
    Mcghee, Steven 19a Canning Street, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mcghee, Steven John 19a Canning Street, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    gb-flag GB Resolis Limited 19 Canning Street, Edinburgh, United Kingdom, EH3 8EG Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 13181806
    gb-flag GB Infrastructure Managers Limited 78 Cannon Street, London, England, EC4N 6AF Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2019 Löschung: 01.04.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05372427
    Johnstone, Peter Kenneth 19a Canning Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2015 Löschung: 30.06.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Wotherspoon, Robert John William Hemel Hempstead Status: Inaktiv Eintragung: 29.09.2009 Löschung: 20.10.2015 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British