USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

HP Nominees Limited

Adresse
Nene House
4 Rushmills
Northampton
NN4 7YB
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 01706320 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussdormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)69102 - Rechtsberatung
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Howes Percival Llp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Oc322781 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Officers (11)

    Quelle: Companies House
    Harris, Andrew David Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB Hp Secretarial Services Limited 4 Rushmills, Northampton, England, NN4 7YB Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 01755417
    Hp Secretarial Services Limited, Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Rolle: Director Nationalität: British
    Maggs, Stuart Peter Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2019 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Tax Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pritchard, Oliver Tim Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Redman, Thomas Keith Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Simmonds, Haydon Anthony Charles Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2024 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Stephen, James David Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Thompson, Matthew Robert Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2014 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Ali, Jahid Ahmed Northampton, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2023 Löschung: 23.11.2023 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB Hp Secretarial Services Limited 4 Rushmills, Northampton, England, NN4 7YB Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2023 Löschung: 04.05.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 01755417

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag GB Howper 2401 Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2023 Companies House Nummer: 15303212 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Howper 2402 Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2023 Companies House Nummer: 15303237 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lorrimar Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02290167 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Milano Estates Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2016 Companies House Nummer: 06655619 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Nelson’S EYE Patch Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2022 Companies House Nummer: 14307591 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Interactive Fish Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2016 Löschung: 17.12.2016 Companies House Nummer: 10277701 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag Interactive Fish Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2016 Löschung: 17.12.2016 Companies House Nummer: 10277694 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as firm
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Simul Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.12.2018 Löschung: 28.01.2019 Companies House Nummer: 11735269 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Wgts Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2021 Löschung: 02.03.2021 Companies House Nummer: 13215649 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors