USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Decantae Mineral Water LTD

Adresse
Unit 39/40
Tir Llwyd Industrial Estate
St Asaph Avenue
Kinmel Bay
LL18 5JA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
30. April 2022
Firmenbuch-Nummer 01949922 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Derby Bar Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2024 Companies House Nummer: 09458456 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Andrews, John Leslie Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2017 Löschung: 12.06.2017 Geburtsdatum: 10.1936 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • gb-flag GB Cott Retail Brands Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2021 Löschung: 23.12.2021 Companies House Nummer: 02865761 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Eden Springs Uk Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.12.2021 Löschung: 25.11.2024 Companies House Nummer: 04063744 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Total Water Solutions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2017 Löschung: 10.03.2021 Companies House Nummer: 09038049 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Nanua, Baljinder Woburn Road Industrial Estate, Kempston, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sidhu, Raminder Singh Woburn Road Industrial Estate, Kempston, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Squire Patton Boggs Secretarial Services Limited, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2017 Rolle: Secretary Nationalität: British
    Ausher, Jason Robert Suite 400, Tampa, United States Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2017 Löschung: 25.11.2024 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Soltis, Brian Macey Birmingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.06.2023 Löschung: 25.11.2024 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    gb-flag GB Squire Patton Boggs Secretarial Services Limited 148 Edmund Street, Birmingham, England, B3 2JR Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2017 Löschung: 25.11.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 02911328