USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Curtis Banks Group Limited

Adresse
Dunn's House
St Paul's Road
Salisbury
SP2 7BF
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 07934492 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Curtis Banks Pension Services Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Nucleus Clyde Acquisition Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Companies House Nummer: 14553187 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as firm
  • Voting rights 75 to 100 percent as firm
  • Right to appoint and remove directors as firm
  • Banks, Christopher Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 04.1949 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (16)

    Quelle: Companies House
    Bruce, Michelle Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Rolle: Secretary
    Clarkson, Alastair James Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2022 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Docherty, Peter Gordon John Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hoskins, Richard Temple Back East, Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Regan, Michael Robert Temple Back East, Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Riley, Cathryn Elizabeth Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Barral, David Barclay Temple Back East, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2022 Löschung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Cowland, Dan James Ipswich, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2019 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Curtis, Rupert Morris Temple Back East, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 06.02.2012 Löschung: 31.12.2018 Beschäftigung: Actuary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Davidson, Judith Mary Temple Back East, Salisbury, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2023 Löschung: 01.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hart, Steven Webster Bristol, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2013 Löschung: 16.12.2014 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mcinnes, Susan Davidson Temple Back East, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2022 Löschung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Millard, Gemma Louise Temple Back East, Bristol, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.05.2023 Löschung: 29.02.2024 Rolle: Secretary
    Mills, Christopher Harwood Bernard Temple Back East, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2022 Löschung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Purves, Kathryn Elizabeth Temple Back East, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2023 Löschung: 20.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Rattray, William John Temple Back East, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2015 Löschung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Curtis Banks Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06758825 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Dunstan Thomas Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Companies House Nummer: 08160246 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Suffolk Life Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2016 Companies House Nummer: 02962287 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Talbot and Muir Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2020 Companies House Nummer: 02869547 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Templemead Property Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2018 Companies House Nummer: 11216858 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB SPS Trustees LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.11.2020 Companies House Nummer: 08312411 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Suffolk Life Annuities Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2019 Löschung: 03.09.2019 Companies House Nummer: 01011674 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag T M Trustees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2020 Löschung: 04.05.2022 Companies House Nummer: 03094287 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag TM Trustees LTD Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2020 Löschung: 04.05.2022 Companies House Nummer: 03094287 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag TM Trustees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2020 Löschung: 04.05.2022 Companies House Nummer: 03094287 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors