USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Code POD Management Limited

Adresse
Bearford House
39 1/2 Hanover Street
Edinburgh
EH2 2PJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
17. Juni 2018
FB Adresse C/O Johnston Carmichael Llp Birchin Court
London
EC3V 9DU
Firmenbuch-Nummer 10675676 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
Landsburgh, Andrew David Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2017 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (2)

    Quelle: Companies House
    Landsburgh, Andrew David Birchin Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2017 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Landsburgh, Louise Birchin Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag Destiny Student England Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2021 Companies House Nummer: 13257789 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Code Concepts Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2023 Löschung: 12.12.2023 Companies House Nummer: 15095779 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors