USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Allison Homes South West Limited

Adresse
Larkfleet House
Falcon Way
Southfields Business Park
Bourne
PE10 0FF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
13. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
22. Juni 2022
FB Adresse Fleet House Cygnet Road
Bourne
PE7 8FD
Firmenbuch-Nummer 07777711 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Larkfleet Homes South West Limited
  • Larkfleet Homes South West L
  • Larkfleet and Dales PV Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Allison Homes Sw Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2018 Companies House Nummer: 10687878 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Larkfleet Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.01.2018 Companies House Nummer: 09610856 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Anderson, John Bruce Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2020 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Brown, Deborah Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2015 Rolle: Secretary
    Fowler, Steven Paul Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jones, Darren Robert Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Trinder, Ian Jens Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Bennett, Matthew Edward Devonshire Gate, Tiverton, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2022 Löschung: 17.11.2023 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wallwork, Paul Antony Hewitt Southfields Business Park, Bourne Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2022 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag GB Hawthorne Gardens Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2018 Companies House Nummer: 11692156 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Ivybridge Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2018 Companies House Nummer: 11692932 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag Lhsw (Churchinford) Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2016 Companies House Nummer: 10115024 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lhsw (Creech ST Michael) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07777676 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lhsw (Ivybridge) Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2017 Companies House Nummer: 11020836 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lhsw Churchinford Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2017 Companies House Nummer: 11035829 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Quantock View Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Companies House Nummer: 12073215 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB The Saxons Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 12930746 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Willow Heights Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2019 Companies House Nummer: 11818913 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control