USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Crescent Estates (Southampton) LTD

Adresse
4 The Mayflowers
Bassett Crescent East
Southampton
Hampshire
SO16 7PD
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
8. Juli 2018
FB Name Crescent Estates (Southampton) Limited
FB Adresse Buildings & Yard Bunny Lane
Eastleigh
SO51 6FT
Firmenbuch-Nummer 00654348 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Pjs One Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2024 Companies House Nummer: 11549973 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Baker, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.10.2019 Geburtsdatum: 03.1935 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Baker, Pauline Mary Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2021 Löschung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 01.1937 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Bath, Jill Kathleen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 05.1948 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Hickox, Richard Norton Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 02.1952 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Short, Christine Joy Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Trustees Of Mr M Baker (Decd.)Will Trust Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2022 Löschung: 31.03.2024 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Street, Michael George Sherfield English, Romsey, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Street, Paul John Sherfield English, Romsey, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Bath, Jill Kathleen Sherfield English, Romsey, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.04.2002 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 05.1948 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hickox, Richard Norton Sherfield English, Romsey, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.04.2002 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 02.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Short, Christine Joy Chandlers Ford, Eastleigh Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2002 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 08.1954 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British