USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Motorman Limited

Adresse
Unit 21-22
North Orbital Commercial Pa
St Albans
Herts
AL1 1XB
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
1. Juli 2021
FB Adresse Synetiq Holdings Ltd Bentley Moor Lane
Doncaster
DN6 7BD
Firmenbuch-Nummer 00945337 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)33170 - Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Synetiq Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2022 Companies House Nummer: 11771655 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Ruddy, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.10.2019 Geburtsdatum: 05.1941 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • gb-flag GB Synetiq Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 16.12.2022 Companies House Nummer: 11771072 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Zalkin, Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.10.2019 Geburtsdatum: 06.1944 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Zalkin, Marion Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.10.2019 Geburtsdatum: 11.1947 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Rumboll, Thomas Charles Adwick-Le-Street, Doncaster, South Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Watt, Darren Adwick-Le-Street, Doncaster, South Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian
    Watt, Darren Adwick-Le-Street, Doncaster, South Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Rolle: Secretary
    Wyant, Sam Adwick-Le-Street, Doncaster, South Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: American
    Jacobs, Eric Adwick-Le-Street, Doncaster, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2023 Löschung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American