USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Beacon LIP LTD

Adresse
Beacon Lip Ltd
Spaces
4500 Solent Business Park
Whiteley, Fareham
PO15 7AZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
7. November 2019
FB Name Beacon LIP Limited
FB Adresse Baird House Seebeck Place
Fareham
MK5 8FR
Firmenbuch-Nummer 10035139 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Beacon Licensed Insolvency Practitioners LLP | Beacon
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Fts Recovery Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Companies House Nummer: 13951545 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Brown, Cheryl Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Fox, Matthew Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2020 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Pretty, James Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.01.2021 Geburtsdatum: 09.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Coleman, Alan Brian Knowlhill, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Licensed Insolvency Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Piacquadio, Marco Knowlhill, Milton Keynes, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB Stelaris Directors Ltd Farringdon, London, England, EC1M 6AW Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 15349718
    Brown, Cheryl Ann East Street, Titchfield, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2016 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Insolvency Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fox, Matthew East Street, Titchfield, Fareham, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2019 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Vine, Philip Martin Solent Business Park, Whiteley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 07.08.2023 Löschung: 28.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British