USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Geschäftsname

Drive Devilbiss Healthcare LTD

Handelsname Drive Devilbiss Healthcare LTD
Adresse
Whitehall 26 Business Park
Heathfield Lane
Birkenshaw
Bradford
BD11 2HW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
8. Dezember 2017
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
15. Juni 2018
Firmenbuch-Nummer 04301005 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen
  • Drive Medical Limited | Medicare Technology
  • Drive Devilbiss Healthcare LTD Drive Devilbiss Healthcare LTD
  • Drive Medical Limited
  • Medicare Technology Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Cd&R Reign Topco Inc Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2017 Art der Kontrolle
  • Right to appoint and remove directors as firm
  • Significant influence or control as firm
  • gb-flag GB Drive International, Llc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.01.2017 Companies House Nummer: 05263486 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Abrahams, Grant Holmfield, Halifax, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2017 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Retail Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Adams, Simon Charles Rouen Holmfield, Halifax, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Adams, Simon Charles Rouen Holmfield, Halifax, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Rolle: Secretary
    Hartley, Gemma Holmfield, Halifax, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2018 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Service Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mcgleenan, Richard James Holmfield, Halifax, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2001 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Thompson, Mark Holmfield, Halifax, England Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2002 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Newby, Timothy Holmfield, Halifax, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2016 Löschung: 08.08.2024 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

    gb-flag GB Aquajoy Bathlifts Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Companies House Nummer: 04366923 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag Mountway Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Companies House Nummer: 07811070 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag Mountway Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Companies House Nummer: 01594500 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag Park House Health Care LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01831906 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Sidhil Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2017 Companies House Nummer: 09553495 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag Specialised Orthotic Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2018 Companies House Nummer: 02996918 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more