USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Flag Atlantic UK LTD

Adresse
World Business Centre 2
Newall Road
London Heathrow Airport
Hounslow
TW6 2SF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
5. Juli 2016
FB Name Flag Atlantic UK Limited
FB Adresse Building 7 Fifth Floor (South),
London
W4 5YG
Firmenbuch-Nummer 03765265 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)61100 - Leitungsgebundene Telekommunikation
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House
Ambani, Anil Dhirubhai Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.03.2019 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Flag Telecom Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2023 Löschung: 08.09.2023 Companies House Nummer: 00055451 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (2)

    Quelle: Companies House
    Kneller, Bradley Peter Chiswick Park, 566 Chiswick High Road,, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: British
    Silkin, Victor Chiswick Park, 566 Chiswick High Road,, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2020 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British